Kentucky, USA



 


Tree: MontyHistNotes_2014

Latitude: 37.825, Longitude: -84.2333


Birth

Matches 1 to 50 of 109

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Young, Masilda  1809Kentucky, USA I4545 MontyHistNotes_2014 
2 Yoakum, Katherine Kitty  24 Mar 1802Kentucky, USA I36012 MontyHistNotes_2014 
3 Woods, Dwight  1873Kentucky, USA I63626 MontyHistNotes_2014 
4 Wilson, Mary  20 Oct 1813Kentucky, USA I35628 MontyHistNotes_2014 
5 Williams, Gertrude T  Abt 1885Kentucky, USA I37292 MontyHistNotes_2014 
6 Wilkins, Virginia Elizabeth  28 Dec 1840Kentucky, USA I504 MontyHistNotes_2014 
7 Wilkins, Louisiana Artemissa  7 Oct 1847Kentucky, USA I358 MontyHistNotes_2014 
8 Wilkins, James Asaph  23 Feb 1859Kentucky, USA I503 MontyHistNotes_2014 
9 Wilkins, Indiana Asenth  26 Jan 1852Kentucky, USA I500 MontyHistNotes_2014 
10 Wilkins, Florida Jane  Nov 1854Kentucky, USA I501 MontyHistNotes_2014 
11 Wilkins, Clinton Jetton  24 Mar 1856Kentucky, USA I502 MontyHistNotes_2014 
12 WIlcoxson, Isham F Sr  11 Mar 1867Kentucky, USA I18227 MontyHistNotes_2014 
13 Waters, Sarah E  Sep 1869Kentucky, USA I5821 MontyHistNotes_2014 
14 Wallace, Finis Talmar  18 Dec 1872Kentucky, USA I59658 MontyHistNotes_2014 
15 Walker, Jennie  Abt 1903Kentucky, USA I37289 MontyHistNotes_2014 
16 Vance, Grace M  6 Nov 1889Kentucky, USA I35197 MontyHistNotes_2014 
17 Stoll, May Craig  8 Feb 1898Kentucky, USA I59692 MontyHistNotes_2014 
18 Stine, Susan  Abt 1863Kentucky, USA I53380 MontyHistNotes_2014 
19 Stine, Julia  Abt 1861Kentucky, USA I53379 MontyHistNotes_2014 
20 Stine, Fred  Abt 1867Kentucky, USA I53381 MontyHistNotes_2014 
21 Stevens, Dora Josephine Jane  3 Jan 1875Kentucky, USA I36510 MontyHistNotes_2014 
22 Smiley, Nancy Ann  17 Oct 1870Kentucky, USA I32456 MontyHistNotes_2014 
23 Shannon, Thomas  1775Kentucky, USA I20155 MontyHistNotes_2014 
24 Rodgers, Thomas Tommie Lee  28 Apr 1870Kentucky, USA I13843 MontyHistNotes_2014 
25 Rodgers, John L  1868Kentucky, USA I13847 MontyHistNotes_2014 
26 Riddle, Helen Talmadge  14 Feb 1931Kentucky, USA I24556 MontyHistNotes_2014 
27 Reynolds, Fannie  27 Oct 1855Kentucky, USA I44706 MontyHistNotes_2014 
28 Ranson, William Wallace  1854Kentucky, USA I20117 MontyHistNotes_2014 
29 Ramer, John Wesley  1798Kentucky, USA I38248 MontyHistNotes_2014 
30 Prichard, Benjamin William  27 Sep 1863Kentucky, USA I67898 MontyHistNotes_2014 
31 Plasters, Elizabeth  1814Kentucky, USA I19178 MontyHistNotes_2014 
32 Pierson, Isaac Pennington  8 Jul 1820Kentucky, USA I4732 MontyHistNotes_2014 
33 Peters, Ellis Lawrence Sr  10 Jan 1904Kentucky, USA I47664 MontyHistNotes_2014 
34 Page, Sarah Angeline  Dec 1857Kentucky, USA I19169 MontyHistNotes_2014 
35 Odor, Artie Caldwell  1882Kentucky, USA I31922 MontyHistNotes_2014 
36 Montgomery, William  1801Kentucky, USA I18088 MontyHistNotes_2014 
37 Montgomery, Thomas  Oct 1890Kentucky, USA I53801 MontyHistNotes_2014 
38 Montgomery, Sarah  Abt 1796Kentucky, USA I17887 MontyHistNotes_2014 
39 Montgomery, Sally C  Abt 1875Kentucky, USA I53800 MontyHistNotes_2014 
40 Montgomery, Nancy  1795Kentucky, USA I18095 MontyHistNotes_2014 
41 Montgomery, Mertie  1894Kentucky, USA I44709 MontyHistNotes_2014 
42 Montgomery, Martha Patsy J  Abt 1867Kentucky, USA I54374 MontyHistNotes_2014 
43 Montgomery, Manuel Clark  28 Jun 1911Kentucky, USA I44704 MontyHistNotes_2014 
44 Montgomery, Joseph G  1865Kentucky, USA I54364 MontyHistNotes_2014 
45 Montgomery, James Sr  1795Kentucky, USA I28509 MontyHistNotes_2014 
46 Montgomery, Effie  1888Kentucky, USA I44708 MontyHistNotes_2014 
47 Montgomery, Edmond H  1863Kentucky, USA I54363 MontyHistNotes_2014 
48 Montgomery, Dollie  1886Kentucky, USA I44707 MontyHistNotes_2014 
49 Montgomery, David  1794Kentucky, USA I25053 MontyHistNotes_2014 
50 Montgomery, Cornelius  1887Kentucky, USA I44702 MontyHistNotes_2014 

1 2 3 Next»



Death

Matches 1 to 19 of 19

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Winston, Martha Patsey  1891Kentucky, USA I53803 MontyHistNotes_2014 
2 Wilkins, Virginia Elizabeth  5 Mar 1871Kentucky, USA I504 MontyHistNotes_2014 
3 Wallace, Samuel  1800Kentucky, USA I34227 MontyHistNotes_2014 
4 Wallace, Margaret  3 Sep 1838Kentucky, USA I64507 MontyHistNotes_2014 
5 Wallace, John  1863Kentucky, USA I47835 MontyHistNotes_2014 
6 Sullivan, Jackie Chas  2 Feb 2012Kentucky, USA I62457 MontyHistNotes_2014 
7 Stine, Frederick Adolphus Jr  15 Aug 1909Kentucky, USA I3175 MontyHistNotes_2014 
8 Shearer, Martha Montgomery  30 Jan 1824Kentucky, USA I3360 MontyHistNotes_2014 
9 Shannon, John  Kentucky, USA I20157 MontyHistNotes_2014 
10 Pennington, Purity Ruffin  Kentucky, USA I4693 MontyHistNotes_2014 
11 Noel, Loftus  Kentucky, USA I9727 MontyHistNotes_2014 
12 Montgomery, Elizabeth  Apr 1834Kentucky, USA I226 MontyHistNotes_2014 
13 Kavanaugh, Delaney Miller  Bef 1907Kentucky, USA I15719 MontyHistNotes_2014 
14 Houston, Captain William L Sr  Aft 1797Kentucky, USA I266 MontyHistNotes_2014 
15 Espy, Ann  Kentucky, USA I9728 MontyHistNotes_2014 
16 Dunbar, Nancy  14 Nov 1853Kentucky, USA I48316 MontyHistNotes_2014 
17 Alexander, John  1834Kentucky, USA I64508 MontyHistNotes_2014 
18 Alexander, Amanda  5 Jun 1856Kentucky, USA I388 MontyHistNotes_2014 
19 Alexander, Abel  1813Kentucky, USA I5189 MontyHistNotes_2014 

Burial

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Smith, Reverend Ensign James  1798Kentucky, USA I33023 MontyHistNotes_2014 
2 Matheny, Donald Eugene  Aug 2002Kentucky, USA I7108 MontyHistNotes_2014 

Military Service

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Military Service    Person ID   Tree 
1 Stevens, Jacob Elijah Sole  1863Kentucky, USA I1232 MontyHistNotes_2014 
2 Parks, Rufus Burton (Xfer)  10 Mar 1862Kentucky, USA I33493 MontyHistNotes_2014 

Relocated

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Relocated    Person ID   Tree 
1 Montgomery, Joseph  Abt 1770Kentucky, USA I18099 MontyHistNotes_2014 
2 Montgomery, Elizabeth  1797Kentucky, USA I226 MontyHistNotes_2014 
3 Houston, Captain William L Sr  1797Kentucky, USA I266 MontyHistNotes_2014 

Marriage

Matches 1 to 5 of 5

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 Oxer / Ewing  1 Jan 1815Kentucky, USA F7801 MontyHistNotes_2014 
2 Minor / Williams  Abt 1950Kentucky, USA F42114 MontyHistNotes_2014 
3 McPheeters / Garrison  20 Jun 1825Kentucky, USA F15060 MontyHistNotes_2014 
4 Finn / Alexander  1865Kentucky, USA F5654 MontyHistNotes_2014 
5 Caldwell / Odor  Between 1901 and 1903Kentucky, USA F12464 MontyHistNotes_2014