Kentucky, USA



 


Tree: MontyHistNotes_2014

Latitude: 37.825, Longitude: -84.2333


Birth

Matches 51 to 100 of 109

«Prev 1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
51 Lovett, Maud  Feb 1886Kentucky, USA I37287 MontyHistNotes_2014 
52 Lovett, Ruth  11 Apr 1902Kentucky, USA I37293 MontyHistNotes_2014 
53 Maple, Ida Mae  3 Oct 1896Kentucky, USA I2959 MontyHistNotes_2014 
54 McCarley, Sarah  1807Kentucky, USA I57113 MontyHistNotes_2014 
55 Miley, Martha F  6 Jan 1893Kentucky, USA I45990 MontyHistNotes_2014 
56 Millsaps, Agnes Nancy  1803Kentucky, USA I25052 MontyHistNotes_2014 
57 Millsaps, Elizabeth  1801Kentucky, USA I18087 MontyHistNotes_2014 
58 Millsaps, Josiah  Abt 1821Kentucky, USA I53171 MontyHistNotes_2014 
59 Montgomery, Canada  Abt 1800Kentucky, USA I18096 MontyHistNotes_2014 
60 Montgomery, Cornelius  1887Kentucky, USA I44702 MontyHistNotes_2014 
61 Montgomery, David  1794Kentucky, USA I25053 MontyHistNotes_2014 
62 Montgomery, Dollie  1886Kentucky, USA I44707 MontyHistNotes_2014 
63 Montgomery, Edmond H  1863Kentucky, USA I54363 MontyHistNotes_2014 
64 Montgomery, Effie  1888Kentucky, USA I44708 MontyHistNotes_2014 
65 Montgomery, James Sr  1795Kentucky, USA I28509 MontyHistNotes_2014 
66 Montgomery, Joseph G  1865Kentucky, USA I54364 MontyHistNotes_2014 
67 Montgomery, Manuel Clark  28 Jun 1911Kentucky, USA I44704 MontyHistNotes_2014 
68 Montgomery, Martha Patsy J  Abt 1867Kentucky, USA I54374 MontyHistNotes_2014 
69 Montgomery, Mertie  1894Kentucky, USA I44709 MontyHistNotes_2014 
70 Montgomery, Nancy  1795Kentucky, USA I18095 MontyHistNotes_2014 
71 Montgomery, Sally C  Abt 1875Kentucky, USA I53800 MontyHistNotes_2014 
72 Montgomery, Sarah  Abt 1796Kentucky, USA I17887 MontyHistNotes_2014 
73 Montgomery, Thomas  Oct 1890Kentucky, USA I53801 MontyHistNotes_2014 
74 Montgomery, William  1801Kentucky, USA I18088 MontyHistNotes_2014 
75 Odor, Artie Caldwell  1882Kentucky, USA I31922 MontyHistNotes_2014 
76 Page, Sarah Angeline  Dec 1857Kentucky, USA I19169 MontyHistNotes_2014 
77 Peters, Ellis Lawrence Sr  10 Jan 1904Kentucky, USA I47664 MontyHistNotes_2014 
78 Pierson, Isaac Pennington  8 Jul 1820Kentucky, USA I4732 MontyHistNotes_2014 
79 Plasters, Elizabeth  1814Kentucky, USA I19178 MontyHistNotes_2014 
80 Prichard, Benjamin William  27 Sep 1863Kentucky, USA I67898 MontyHistNotes_2014 
81 Ramer, John Wesley  1798Kentucky, USA I38248 MontyHistNotes_2014 
82 Ranson, William Wallace  1854Kentucky, USA I20117 MontyHistNotes_2014 
83 Reynolds, Fannie  27 Oct 1855Kentucky, USA I44706 MontyHistNotes_2014 
84 Riddle, Helen Talmadge  14 Feb 1931Kentucky, USA I24556 MontyHistNotes_2014 
85 Rodgers, John L  1868Kentucky, USA I13847 MontyHistNotes_2014 
86 Rodgers, Thomas Tommie Lee  28 Apr 1870Kentucky, USA I13843 MontyHistNotes_2014 
87 Shannon, Thomas  1775Kentucky, USA I20155 MontyHistNotes_2014 
88 Smiley, Nancy Ann  17 Oct 1870Kentucky, USA I32456 MontyHistNotes_2014 
89 Stevens, Dora Josephine Jane  3 Jan 1875Kentucky, USA I36510 MontyHistNotes_2014 
90 Stine, Fred  Abt 1867Kentucky, USA I53381 MontyHistNotes_2014 
91 Stine, Julia  Abt 1861Kentucky, USA I53379 MontyHistNotes_2014 
92 Stine, Susan  Abt 1863Kentucky, USA I53380 MontyHistNotes_2014 
93 Stoll, May Craig  8 Feb 1898Kentucky, USA I59692 MontyHistNotes_2014 
94 Vance, Grace M  6 Nov 1889Kentucky, USA I35197 MontyHistNotes_2014 
95 Walker, Jennie  Abt 1903Kentucky, USA I37289 MontyHistNotes_2014 
96 Wallace, Finis Talmar  18 Dec 1872Kentucky, USA I59658 MontyHistNotes_2014 
97 Waters, Sarah E  Sep 1869Kentucky, USA I5821 MontyHistNotes_2014 
98 WIlcoxson, Isham F Sr  11 Mar 1867Kentucky, USA I18227 MontyHistNotes_2014 
99 Wilkins, Clinton Jetton  24 Mar 1856Kentucky, USA I502 MontyHistNotes_2014 
100 Wilkins, Florida Jane  Nov 1854Kentucky, USA I501 MontyHistNotes_2014 

«Prev 1 2 3 Next»