Search
First Name:
Last Name:
Advanced Search
Surnames
Log In
What's New
Most Wanted
Documents
Headstones
Histories
Photos
Recordings
Videos
Census
Certificate
Folios
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Documents
Headstones
Histories
Photos
Recordings
Videos
Census
Certificate
Folios
Albums
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Share
Print
Bookmark
William Wyncelow
1375 - 1426 (51 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
William Wyncelow
[1]
b. 1375 d. 1426
Agnes Poore
b. 1379 d. 1443
2
John Wyncelow
[1.1]
b. 1400 d. 31 Mar 1463
Agnes Throckmorton
b. 1420 d. 1463
3
Thomas Winslow
[1.1.1]
b. 1452 d. 1507
Lady Cecilla Lady Agnes Tansley
b. 1478 d. 1515
4
William Winslow
[1.1.1.1]
b. 1510 d. 1529
Mary Bucke
b. 1505 d. 1560
5
Kenelm Winslow
[1.1.1.1.1]
b. 1528 bur. 9 Nov 1607
Catherine Winslow
b. 1535 d. 1629
6
Edward Winslow
[1.1.1.1.1.1]
b. 17 Oct 1560 d. 1620
Magdalene Oliver
b. 4 Aug 1566 d. 24 Mar 1621
7
John Winslow
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 16 Apr 1597 d. 21 May 1674
7
Eleanor Winslow
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 22 Apr 1598 d. 1672
7
Kenelm Winslow
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 29 Apr 1599 d. 13 Sep 1672
7
Gilbert Winslow
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 26 Oct 1600 d. 26 Oct 1660
7
Elizabeth Winslow
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 6 Mar 1603 d. 20 Jan 1605
7
Josiah Winslow
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 11 Feb 1606 d. 1 Dec 1674
7
Mary Magdalene Winslow
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 24 Dec 1610 d. 26 Mar 1687
Peter Worden
b. 1609 d. 11 Jan 1680
8
Mary Worden
[1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 10 Feb 1639 d. 1723
John Burgess
b. 10 Feb 1628 d. 17 Mar 1719
9
Mary Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 1658 d. 1717
Manoah Mathias Ellis, Sr
b. 2 Jun 1657 d. 30 Aug 1748
10
Captain Joel Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 17 Jan 1679 d. 21 Jun 1763
+
Elizabeth Churchill
b. 7 Oct 1687 d. 3 Apr 1753
10
Manoah Mathias Ellis, Jr
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.2]
b. 1682 d. 2 Dec 1726
Elizabeth Atkins
b. 1685 d. 2 Dec 1726
11
Joshua Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.2.1]
b. 1711 d. 1790
Thankful Nickerson
b. 26 Jul 1705 d. 1769
12
Nathaniel Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.2.1.1]
b. 1734 d. 1794
10
Cornelius Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3]
b. 1684 d. 7 May 1729
+
Mercy Atkins
b. 24 Nov 1686 d. 7 May 1729
10
Mercy Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.4]
b. 17 Aug 1685 d. Bef 30 Oct 1751
+
Thomas Doty
b. 22 Jul 1679 d. 22 Feb 1721
+
Jonathan Barnes
b. 27 Aug 1684 d. 27 Dec 1736
10
Elnathan Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.5]
b. 1686 d. 3 Jun 1730
+
Mary Burgess
b. 25 Dec 1695 d. 3 Jun 1730
10
Expericne Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6]
b. 26 Jul 1687 d. Sep 1751
+
Stephen Churchill
b. 16 Feb 1685 d. 6 Oct 1750
10
Samuel Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7]
b. 1688 d. 1760
+
Thankful Smith
b. 14 Jul 1698 d. 31 Dec 1724
Mary Eldredge
b. 1720 d. 30 Aug 1808
11
Gideon Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1]
b. 21 Jun 1759 d. 10 Jul 1841
Zillah Merrill
b. 26 Mar 1760 d. 26 Apr 1840
12
Kimble Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.1]
b. 15 Apr 1779 d. 12 Feb 1813
12
Samuel Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.2]
b. 1781 d. 1830
12
Desire Harriet Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.3]
b. 6 May 1783 d. 10 Apr 1860 [
=>
]
12
Gideon Ellis, Jr
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.4]
b. 27 Dec 1785 d. 7 Jan 1813
12
Calvin Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.5]
b. 2 May 1788 d. 8 Feb 1813
12
Walter Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.6]
b. 1792 d. 2 Feb 1813
12
Reuben Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.7]
b. 25 Sep 1794 d. 14 Apr 1830
12
Lyman Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.8]
b. 13 Feb 1797 d. 17 Feb 1837
12
Abigail B Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.9]
b. 3 Apr 1799 d. 31 Dec 1853
12
Harvey Lewis Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.10]
b. 26 May 1801 d. 14 Apr 1868
12
Darius L Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.11]
b. 11 Mar 1804 d. 3 Jun 1804
11
Absalom Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.2]
b. 20 Aug 1761 d. 1816
Abigail Wood
b. 1771 d. 3 Aug 1833
12
James Tillman Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.2.1]
b. 1791 d. 1878
12
Thomas Weld Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.2.2]
b. 24 Apr 1799 d. 3 Aug 1859 [
=>
]
12
Isaac Ellis
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.2.3]
b. 7 Jul 1803 d. 21 Dec 1877 [
=>
]
12
Absalom Ellis, Jr
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.2.4]
b. 1804 d. 1835
9
John Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 1663 d. 4 Feb 1723
Sarah Nickerson
b. 1 May 1674 d. 4 Feb 1722
10
Mary Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.1]
b. 25 Dec 1695 d. 3 Jun 1730
+
Elnathan Ellis
b. 1686 d. 3 Jun 1730
10
Elizabeth Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2]
b. 12 Oct 1697
+
Prince Wixon
10
Joseph Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3]
b. 9 Jul 1699
10
Benjamin Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4]
b. 3 May 1701
10
Samuel Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.5]
b. 3 Feb 1703
10
Ezekiel Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.6]
b. 9 Aug 1704
10
Thankful Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.7]
b. 7 Jun 1708
+
John Blossom
b. Abt 1707
10
John Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.8]
b. Oct 1710
9
Thomas Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 1666 d. 1737
+
Sarah Storrs
b. 26 Jun 1670 d. 1737
9
Joseph Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. Abt 1670
9
Martha Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 1671 d. 3 Sep 1728
+
Samuel Storrs
b. Abt 1670
9
Patience Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 1672 d. 1744
+
Nye
b. Abt 1671
9
Jacob Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.7]
b. Abt 1673
9
Samuel Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.8]
b. Abt 1674
9
Mercy Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.9]
b. Abt 1675
+
Winslow
b. Abt 1675
9
Sarah Burgess
[1.1.1.1.1.1.7.1.10]
b. Abt 1676
+
Eleanor Pelham
Catherine Bucke
b. 1530 d. 4 Apr 1607
6
John Winslow
[1.1.1.1.1.2]
b. Abt 1562
6
Richard Winslow
[1.1.1.1.1.3]
b. 1590 d. 20 May 1659
5
Richard Winslow
[1.1.1.1.2]
b. 17 Jul 1530 d. 1610